Affichage de 413487 résultats

Sujets
Sujets terme Note sur la portée et contenu description archivistique décompte fichier d'autorité décompte
Jan Martense Schenck House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Schenck House (New York, N.Y.)

0 0
George B. and Susan Elkins House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Elkins House (New York, N.Y.)

0 0
James W. and Lucy S. Elwell House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Elwell House (New York, N.Y.), James W. Elwell House (New York, N.Y.)

0 0
415 Westervelt Avenue (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Sans titre

0 0
Henry Lloyd Manor House (Huntington, N.Y.)

Utilisé pour : Lloyd Manor House (Huntington, N.Y.)

0 0
511 Grand Street (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Five hundred eleven Grand Street (New York, N.Y.)

0 0
Seaman Cottage (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Henry Seaman Cottage (New York, N.Y.)

0 0
Osborne House (Victor, N.Y.)

Utilisé pour : D. H. Osborne House (Victor, N.Y.)

0 0
Edgewater (N.Y.)

Utilisé pour : Sans titre

0 0
Dr. Samuel MacKenzie Elliott House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Samuel MacKenzie Elliott House (New York, N.Y.), Doctor Samuel MacKenzie Elliott House (New York, N.Y.), Elliott House (New York, N.Y.)

0 0
H.H. Richardson House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Richardson House (New York, N.Y.)

0 0
314 East 53rd Street House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Sans titre

0 0
Rock Hall (Lawrence, N.Y.)

Utilisé pour : Sans titre

0 0
Samuel Pell House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Pell House (New York, N.Y.)

0 0
Wyckoff-Bennett Homestead (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Bennett-Wyckoff Homestead (New York, N.Y.)

0 0
John H. and Elizabeth J. Elsworth House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Elsworth House (New York, N.Y.), Ellsworth House (New York, N.Y.), John H. Ellsworth House (New York, N.Y.)

0 0
Frederick C. and Birdsall Otis Edey Residence (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Edey Residence (New York, N.Y.), Birdsall Otis Edey House (New York, N.Y.), Birdsall and Frederick Edey Residence (New York, N.Y.)

0 0
M'Clintock House (Waterloo, N.Y.)

Utilisé pour : McClintock House (Waterloo, N.Y.), Mary Ann McClintock House (Waterloo, N.Y.), Mary Ann M'Clintock House (Waterloo, N.Y.)

0 0
Rose Hill (N.Y.)

Utilisé pour : Sans titre

0 0
Villa Lewaro (Irvington, N.Y.)

Utilisé pour : Lewaro Villa (Irvington, N.Y.)

0 0
504 Canal Street House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Sans titre

0 0
480 Greenwich Street/502 Canal Street House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : 502 Canal Street House (New York, N.Y.), John Y. Smith House (New York, N.Y.)

0 0
James F.D. Lanier Residence (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Lanier House (New York, N.Y.), James F.D. Lanier House (New York, N.Y.), James F.D. and Harriet Lanier House (New York, N.Y.), Lanier Residence (New York, N.Y.)

0 0
Williamsbridge Reservoir Keeper's House (New York, N.Y.)

Utilisé pour : Reservoir Keeper's House on Reservoir Oval (New York, N.Y.), Keeper's House at the Former Williamsbridge Reservoir (New York, N.Y.), Keeper's House at Williamsbridge Reservoir (New York, N.Y.)

0 0
Gilman Garrison House (Exeter, N.H.)

Utilisé pour : Garrison House (Exeter, N.H.), Garrison Gilman House (Exeter, N.H.)

0 0
John Alden House (Duxbury, Mass.)

Utilisé pour : Alden House (Duxbury, Mass.)

0 0
Pierce-Hichborn House (Boston, Mass.)

Utilisé pour : Nathaniel Hichborn House (Boston, Mass.), Hichborn House (Boston, Mass.), Moses Pierce House (Boston, Mass.)

0 0
Greater Light (Nantucket, Mass.)

Utilisé pour : Sans titre

0 0
Salisbury Mansion (Worcester, Mass.)

Utilisé pour : Sans titre

0 0
Grange (Lincoln, Mass.)

Utilisé pour : Chambers-Russell-Codman House (Lincoln, Mass.), The Grange (Lincoln, Mass.)

0 0
Résultats 181 à 210 sur 413487